-
-
MECOMO AG - Max-Planck-Str. 8, 85716 Unterschleißheim, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB134621 MÜNCHEN
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Max-Planck-Str. 8
- 85716 Unterschleißheim Max-Planck-Str. 8, 85716 Unterschleißheim DE
Management
- Company secretaries
- Monika Irmgard Theresia Röck (Prokura)
- Julija Bednarz (Prokura)
- Johannes Kroll (Prokura)
- Christian Langowski (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Aktiengesellschaft
- Incorporated
- 2000-12-07
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 2000-12-07 25 years
Ownership
- Share Capital
- 350.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- -
- -
- Court
- DE/München
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 54930007N1JQKVJL6U48
- VAT Number
- DE813084830
- Website
- www.mecomo.com
- Email address
- [email protected]
- Phone
- 089/3740850
- Fax
- 089/37408545
-
MECOMO AG Company Description
- www.mecomo.com.
Get MECOMO AG Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Mecomo Ag - Max-Planck-Str. 8, 85716 Unterschleißheim, Germany
- 2000-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2023-09-27 Modification
- Dem Amtsgericht München -Registergericht- ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht worden, § * AktG.
-
MECOMO AG
Did you know? kompany provides original and official company documents for MECOMO AG as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2021
-
2021-01-28 - Anmeldung vom 28.01.2021
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-05-09 - Anmeldung vom 09.05.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-12-08 - Anmeldung vom 08.12.2017
-
2017-11-22 - Amtsniederlegung vom 22.11.2017
-
2017-04-18 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 18.04.2017
-
2017-06-27 - Anmeldung vom 27.06.2017
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-07-29 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 29.07.2016
-
2016-08-25 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.08.2016
-
2016-08-25 - Anmeldung vom 25.08.2016
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-08-10 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.08.2014
-
2014-01-09 - Anmeldung vom 09.01.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-12-20 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 20.12.2013
-
2013-11-18 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 18.11.2013
-
2013-05-27 - Anmeldung vom 27.05.2013
-
2013-12-20 - Anmeldung vom 20.12.2013
-
2013-12-16 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 16.12.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-01-03 - Anmeldung vom 03.01.2012
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-05-14 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 14.05.2011
-
2011-12-23 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 23.12.2011
-
2011-12-12 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.12.2011
-
2011-07-20 - Anmeldung vom 20.07.2011
-
2011-12-28 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 28.12.2011
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-02-13 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 13.02.2009
-
2009-12-15 - Anmeldung vom 15.12.2009
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-05-21 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 21.05.2007