• DE
  • JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH - Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim, Germany

Company Information

Company registration number
HRB253278 STUTTGART
Company Status
LIVE
Country
Germany
Registered Address
Gutenbergstraße 16
71277 Rutesheim
Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim DE

Management

Managing Directors
Torsten Winterwerber (Geschaeftsfuehrer)
Johannes Klein (Geschaeftsfuehrer)
Uwe Stichelen (Geschaeftsfuehrer)
Jürgen Elsäßer (Geschaeftsfuehrer)
Andreeas Thierer (Geschaeftsfuehrer)
Sven Schwab (Geschaeftsfuehrer)

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
1979-09-06
Dissolved on
-
Age Of Company
1979-09-06 44 years

Ownership

Share Capital
1.250.000,00 EUR

Jurisdiction Particularities

Additional Status Details
aktuell
Court
DE/Stuttgart
Legal Entity Identifier (LEI)
529900YICG559HDVPP87
VAT Number
DE132085486
Website
https://www.joysonquin.com
email address
info@joysonquin.com
Phone
+49 7152330020
Fax
+49 715233002120

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH Company Description

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB253278 STUTTGART. Its current trading status is "live". It was registered 1979-09-06. The managing director is Torsten Winterwerber,Johannes Klein,Uwe Stichelen,Jürgen Elsäßer,Andreeas Thierer,Sven Schwab.It can be contacted at Gutenbergstraße 16 by phone on +49 7152330020 by email at info@joysonquin.com by fax on +49 715233002120 on the web at https://www.joysonquin.com.
More information

Get JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract

You are here: Joysonquin Automotive Systems Gmbh - Gutenbergstraße 16, 71277 Rutesheim, Germany

1979-09-06 44 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Handelsregister

  • 2022-07-07 Modification
    • HRB *: JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH, Gutenbergstr. *, D- * Rutesheim. Bestellt als Geschäftsführer: Schwab, Sven, Saalfeld, **.*.*.
    • 2022-01-25 Modification
      • HRB *: JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH, Rutesheim, Gutenbergstr. *, D-* Rutesheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Vander Stichelen, Uwe, Herne, **.*.*.
    • 2019-03-22 Modification
      • HRB *: Quin GmbH, Rutesheim, Gutenbergstraße *, * Rutesheim. Die Gesellschafterversammlung vom *.*.* hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § * Abs.* (Firma) beschlossen. Firma geändert, nun: JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Add to Cart
     

    Register Report

    Official proof of the company existence

    Add to Cart
     

    Shareholder List

    Details on the shareholders

    Add to Cart
     

    Articles of Association

    Founding documents

    Add to Cart
     

    Annual Account

    Financial data for the last reported full year

    Add to Cart
     

    Chronological Extract

    Full record of registrable changes

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2020-02-05 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 05.02.2020

      Add to Cart
       
    • 2130-10-26 - Dauervollmacht vom 26.10.2130

      Add to Cart
       
    • 2019-11-06 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 06.11.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-01-31 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 31.01.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-01-30 - Einzelvollmacht vom 30.01.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-01-31 - Anmeldung vom 31.01.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-01-31 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 31.01.2019

      Add to Cart
       
    • 2018-01-11 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 11.01.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-05-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.05.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-03-om 01 - => Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 01.03.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-04-16 - Vertretungsnachweis vom 16.04.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-06-12 - Amtsniederlegung vom 12.06.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-06-14 - Anmeldung vom 14.06.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-06-14 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 14.06.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-03-ed 01 - => Report - decision - record dated 01-03-2018

      Add to Cart
       
    • 2018-05-08 - Anmeldung vom 08.05.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-11-07 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 07.11.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-10-18 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 18.10.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-11-07 - Vertretungsnachweis vom 07.11.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-11-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.11.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-05-18 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 18.05.2018

      Add to Cart
       
    • 2018-11-07 - Anmeldung vom 07.11.2018

      Add to Cart
       
    • 2017-02-01 - Anmeldung vom 01.02.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-01-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.01.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-01-10 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 10.01.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-26 - Anmeldung vom 26.09.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-08-01 - Anmeldung vom 01.08.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-10-26 - Dauervollmacht vom 26.10.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-29 - Anmeldung vom 29.09.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-om 26 - => Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.09.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-29 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 29.09.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-09-ed 26 - => Report - decision - record dated 26-09-2017

      Add to Cart
       
    • 2017-06-12 - Anmeldung vom 12.06.2017

      Add to Cart
       
    • 2017-05-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.05.2017

      Add to Cart
       
    • 2016-10-27 - Anmeldung vom 27.10.2016

      Add to Cart
       
    • 2016-09-12 - Anmeldung vom 12.09.2016

      Add to Cart
       
    • 2016-04-14 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 14.04.2016

      Add to Cart
       
    • 2016-11-04 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 04.11.2016

      Add to Cart
       
    • 2016-11-04 - Dauervollmacht vom 04.11.2016

      Add to Cart
       
    • 2015-01-20 - Anmeldung vom 20.01.2015

      Add to Cart
       
    • 2015-01-20 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 20.01.2015

      Add to Cart
       
    • 2015-01-29 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 29.01.2015

      Add to Cart
       
    • 2015-10-29 - Vertretungsnachweis vom 29.10.2015

      Add to Cart
       
    • 2015-01-20 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 20.01.2015

      Add to Cart
       
    • 2014-12-03 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 03.12.2014

      Add to Cart
       
    • 1717-11-04 - Dauervollmacht vom 04.11.1717

      Add to Cart
       
    • 0012-11-07 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 07.11.0012

      Add to Cart
       
    expand_less