• AT
  • STRABAG Property and Facility Services GmbH - Dietrichgasse 25/E-Büro/6.OG, 1030, Wien, AUT, Austria

Company Information

Company registration number
124669m
Company Status
LIVE
Country
Austria
Registered Address
Dietrichgasse 25/E-Büro/6.OG
1030
Wien
AUT
Dietrichgasse 25/E-Büro/6.OG, 1030, Wien, AUT AT

Management

Supervisory Board
Mag. Christian Harder (AUFSICHTSRATSMITGLIED)
Ortenburgerstraße 27, 9800, Spittal an der Drau, AUT
Dipl.Ing. Siegfried Wanker (AUFSICHTSRATSMITGLIED)
Donau-City-Straße 9, 1220, Wien, AUT
Klemens Peter Haselsteiner (AUFSICHTSRATSMITGLIED)
Donau-City-Straße 9, 1220, Wien, AUT
Dipl. Ing. (FH) Jörg Rösler (AUFSICHTSRATSMITGLIED)
Unterstraße 18a, 99867, Gotha, DEU
Dipl.-Ing.(FH) Alfred Watzl (AUFSICHTSRATSMITGLIED)
Donau-City-Straße 9, 1220, Wien, AUT
Managing Directors
Stefan Babsch (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Josef Flansdorfer Straße 57, Haus 23, 1210, Wien, AUT
Mag. Marcus Kaller (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o Leopold-Böhm-Straße 10, Office 1, 4.OG, Top 437-454, 1030, Wien, AUT
Matthias Plattner (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o Leopold-Böhm-Straße 10, Office 1, 4. OG, Top437-454, 1030, Wien, AUT
Company secretaries
Christian Roitner (PROKURIST/IN)
Freyen 9, 3233, Kilb, AUT
Wolfgang Draxler (PROKURIST/IN)
Kaltenbrunnerstraße 58, 8700, Leoben, AUT
Ing. Manfred Woletz (PROKURIST/IN)
Pfalzauerstraße 156, 3021, Pressbaum, AUT
Edith Kraus (PROKURIST/IN)
Bahnzeile 12, 2540, Bad Vöslau, AUT
Mag. Andreas Zeilinger (PROKURIST/IN)
Roseggerstraße 37, 4850, Timelkam, AUT
David Kohlhauser (PROKURIST/IN)
Unterbuch 17, 8274, Buch bei Hartberg, AUT
Andreas Neuninger (PROKURIST/IN)
Kirchengasse 1A/1/5, 2521, Trumau/ Aspangbahn, AUT
Mag. Josef Fink (PROKURIST/IN)
Lutherstraße 7, 9800, Spittal an der Drau, AUT
Christian Horvath (PROKURIST/IN)
Erlengrund 3, 8074, Raaba-Grambach, AUT
Jürgen Pranzl (PROKURIST/IN)
Köbrunnweg 11, 4203, Altenbach bei Linz, AUT
Johannes Booch (PROKURIST/IN)
Weichstetten-Ost 1/1, 4502, St. Marien, AUT

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
1970-03-25
Age Of Company
1970-03-25 54 years

Ownership

Shareholders
STRABAG AG (GESELLSCHAFTER/IN, 1500000 EUR, 100%) Siegburger Straße 241 50679 Köln DEU
Share Capital
1500000 EUR
Paidup Capital
1500000

Jurisdiction Particularities

Court
Handelsgericht Wien
Previous Names
Fach Gesellschaft m.b.H.
Legal Entity Identifier (LEI)
5299008YVFVIDDYCS862
Identnumber
630519
Phone
05 05 99-0

STRABAG Property and Facility Services GmbH Company Description

STRABAG Property and Facility Services GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Austria with the Company reg no FN 124669 m. Its current trading status is "live". It was registered 1970-03-25. It was previously called Fach Gesellschaft m.b.H.. and 11 secretaries. The managing director is Stefan Babsch,Mag. Marcus Kaller,Matthias Plattner.It can be contacted at Dietrichgasse 25/e-Büro/6.og by phone on 05 05 99-0 .
More information

Get STRABAG Property and Facility Services GmbH Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870

You are here: Strabag Property And Facility Services Gmbh - Dietrichgasse 25/E-Büro/6.OG, 1030, Wien, AUT, Austria

1970-03-25 54 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Firmenbuch

  • 2024-04-26 Modification
    • Die Firma mit der offiziellen Registernummer *m hat einen neuen Antrag gestellt. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2023-12-21 Modification
      • Die Firma mit der offiziellen Registernummer *m hat eine Unterschriftenprobe zu Vergleichszwecken eingereicht (Musterzeichnung) und hat eine Änderung in der Gesellschafterstruktur bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2023-07-08 Modification
      • Die Firma mit der offiziellen Registernummer *m hat einen neuen Antrag gestellt und hat eine Unterschriftenprobe zu Vergleichszwecken eingereicht (Musterzeichnung). Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for STRABAG Property and Facility Services GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Add to Cart
     

    Register Report

    Official proof of the company existence

    Add to Cart
     

    Annual Accounts

    Financial data for the last reported full year

    Add to Cart
     

    Articles of Association

    Founding documents

    Add to Cart
     

    Credit Report by KSV1870

    Official credit data

    Add to Cart
     

    Credit Check by KSV1870

    Brief credit details

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2024-04-19 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2023-11-14 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2023-12-12 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2023-07-04 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2023-06-12 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2023-02-14 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2023-01-03 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2022-04-27 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-06-14 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2022-12-08 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2022-12-31 - Lagebericht

      Add to Cart
       
    • 2022-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2022-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2021-07-15 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2021-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2021-12-31 - Lagebericht

      Add to Cart
       
    • 2021-11-16 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-11-18 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2021-07-15 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2020-06-04 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2020-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2020-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2020-12-31 - Lagebericht

      Add to Cart
       
    • 2019-10-25 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-10-25 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2019-09-04 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-12-31 - Lagebericht

      Add to Cart
       
    • 2019-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2019-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2017-10-10 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2016-01-20 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2016-01-18 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-06-01 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2015-10-13 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-03-11 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2015-09-17 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2015-09-17 - Verschmelzungsvertrag

      Add to Cart
       
    • 2015-10-20 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2015-10-16 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2014-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2014-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2014-12-09 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2014-11-03 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2014-10-27 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2014-06-04 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2013-12-05 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2013-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2013-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2012-11-19 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2012-12-05 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2011-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2011-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2011-06-21 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2010-10-01 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2010-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2010-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2010-10-01 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2010-01-14 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2009-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2009-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2009-10-19 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2008-03-11 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2008-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2008-05-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2007-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2007-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2007-10-24 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-09-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2006-09-30 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2006-12-05 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-02-23 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-05-08 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-03-06 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2005-11-29 - Bericht

      Add to Cart
       
    • 2005-11-28 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2004-12-07 - Bericht

      Add to Cart
       
    • 2004-12-02 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       

    expand_less