• AT
  • S 51 Immo GmbH - Schottenbastei 4/7, 1010, Wien, AUT, Austria

Company Information

Company registration number
371390m
Company Status
LIVE
Country
Austria
Registered Address
Schottenbastei 4/7
1010
Wien
AUT
Schottenbastei 4/7, 1010, Wien, AUT AT

Management

Managing Directors
Mag. Andreas Ruthensteiner (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Schottenbastei 4/7, 1010, Wien, AUT
Franz Hartl (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Felix-Mottl-Straße 10, 1190, Wien, AUT
Dr. Alice Hartl-Naumann (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Felix Mottl Straße 10, 1190, Wien, AUT

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
2016-09-13
Age Of Company
2016-09-13 8 years
Activity
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen

Ownership

Shareholders
Franz Hartl (GESELLSCHAFTER/IN, 17500 EUR, 50%) Felix-Mottl-Straße 10 1190 Wien AUT
Dr. Alice Hartl-Naumann (GESELLSCHAFTER/IN, 17500 EUR, 50%) Felix Mottl Straße 10 1190 Wien AUT
Share Capital
35000 EUR
Paidup Capital
35000

Jurisdiction Particularities

Court
Handelsgericht Wien
Identnumber
11192780
Phone
01 513 30 51

S 51 Immo GmbH Company Description

S 51 Immo GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Austria with the Company reg no FN 371390 m. Its current trading status is "live". It was registered 2016-09-13. The declared activity is Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. The managing director is Mag. Andreas Ruthensteiner,Franz Hartl,Dr. Alice Hartl-Naumann.It can be contacted at Schottenbastei 4/7 by phone on 01 513 30 51 .
More information

Get S 51 Immo GmbH Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870

You are here: S 51 Immo Gmbh - Schottenbastei 4/7, 1010, Wien, AUT, Austria

2016-09-13 8 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Firmenbuch

  • 2024-09-06 Modification
    • Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *m wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2023-08-17 Modification
      • Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *m wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2023-04-29 Modification
      • Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *m wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for S 51 Immo GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Register Report

    Sample
    €11.86
    Add to Cart
     

    Official proof of the company existence

    Annual Accounts

    Sample
    €8.65
    Add to Cart
     

    Financial data for the last reported full year

    Articles of Association

    Sample
    €8.65
    Add to Cart
     

    Founding documents

    Credit Report by KSV1870

    Sample
    €37.98
    Add to Cart
     

    Official credit data

    Credit Check by KSV1870

    Sample
    €27.52
    Add to Cart
     

    Brief credit details

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2022-01-24 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2022-01-24 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-01-24 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2022-04-11 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-02-03 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-02-15 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2017-10-16 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-07-31 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2016-07-18 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2016-09-13 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2016-07-31 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2016-07-31 - Ergebnisverwendungsvorschlag

      Add to Cart
       
    • 2016-07-31 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2016-09-13 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2016-09-13 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-10-27 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2015-12-31 - Ergebnisverwendungsvorschlag

      Add to Cart
       
    • 2015-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2015-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2014-06-24 - Beschluss d. Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2014-07-09 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2014-06-24 - Zeichnungsschein

      Add to Cart
       
    • 2014-06-24 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2014-06-24 - Beschluss d. Vorstandes

      Add to Cart
       
    • 2014-10-01 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2014-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2014-12-31 - Ergebnisverwendungsvorschlag

      Add to Cart
       
    • 2014-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2013-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2013-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2013-03-08 - Prüfbericht

      Add to Cart
       
    • 2013-03-19 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2013-03-19 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2013-04-23 - Prüfbericht

      Add to Cart
       
    • 2013-03-19 - Sacheinlagevertrag

      Add to Cart
       
    • 2013-03-19 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2013-03-19 - Zeichnungsschein

      Add to Cart
       
    • 2013-05-08 - Entscheidung des Gerichts

      Add to Cart
       
    • 2013-12-10 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2013-12-10 - Zeichnungsschein

      Add to Cart
       
    • 2013-12-10 - Beschluss d. Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2013-12-10 - Beschluss d. Vorstandes

      Add to Cart
       
    • 2012-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-05-09 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2012-01-17 - Zeichnungsschein

      Add to Cart
       
    • 2012-01-17 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-02-01 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2012-01-17 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2012-04-18 - Zeichnungsschein

      Add to Cart
       
    • 2012-04-11 - Protokoll

      Add to Cart
       
    • 2012-07-03 - Verzeichnis der Zeichner

      Add to Cart
       
    • 2012-07-03 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-09-18 - Bericht

      Add to Cart
       
    • 2012-09-04 - Prüfbericht

      Add to Cart
       
    • 2012-09-20 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2011-11-14 - Satzung

      Add to Cart
       
    • 2011-11-14 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2011-11-14 - Protokoll

      Add to Cart
       
    • 2011-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2011-12-31 - Ergebnisverwendungsvorschlag

      Add to Cart
       
    • 2011-11-14 - Bericht

      Add to Cart
       
    • 2011-11-14 - Prüfbericht

      Add to Cart
       

    expand_less