-
-
Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen - Linzer Straße 6, 3382, Loosdorf/ Bez. Melk, AUT, Austria
Company Information
- Company registration number
- 77781i
- Company Status
- LIVE
- Country
- Austria
- Registered Address
- Linzer Straße 6
- 3382
- Loosdorf/ Bez. Melk
- AUT Linzer Straße 6, 3382, Loosdorf/ Bez. Melk, AUT AT
Management
- Managing Directors
-
Dietmar Schöner (VORSTAND)
Hauptplatz 1, 3240, Mank, AUT -
Dipl.Ing. Gabriele Zehetner (VORSTAND)
Am Bründl 1, 3385, Gerersdorf, AUT -
Margot Schütz (VORSTAND)
Wachaustraße 2, 3385, Prinzersdorf, AUT -
Franz Biber (VORSTAND)
Merkendorf 8, 3382, Loosdorf/ Bez. Melk, AUT -
Dipl.HLFL-Ing. Karl Engelhart, CMC (GESCHÄFTSLEITER/IN)
Dietersbergstraße 3, 3110, Neidling, AUT -
Mag. Dr. Christian Winter (VORSTAND)
Marktplatz 5, 3122, Gansbach, AUT -
Sandra Potzmader (VORSTAND)
Erlaweg 16, 3241, Kirnberg an der Mank, AUT -
Alfons Pitterle, MBA (MCI) (GESCHÄFTSLEITER/IN)
Quellenweg 8, 3233, Kilb, AUT -
Mag. (FH) Markus Zuser (GESCHÄFTSLEITER/IN)
Eibelsau 2, 3384, Groß Sierning, AUT
- Company secretaries
-
Karl Posch (PROKURIST/IN)
Birnengasse 3, 3384, Groß Sierning, AUT -
Mag. Nicola Feichtegger (PROKURIST/IN)
Pfoisau 10, 3281, Oberndorf an der Melk, AUT -
Helga Punz (PROKURIST/IN)
Kerngasse 9, 3382, Mauer, AUT -
Herbert Grasmann (PROKURIST/IN)
Oberdörfl 10/1, 3281, Oberndorf an der Melk, AUT
- Officers
-
RAIFFEISEN-REVISIONSVERBAND (REVISIONSVERBAND)
Hammer-Purgstall-Gasse 6, 1020, Wien, AUT
Company Details
- Type of Business
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
- Incorporated
- 1892-11-02
- Age Of Company 1892-11-02 132 years
Ownership
- Share Capital
- 8 EUR
Jurisdiction Particularities
- Court
- Landesgericht St. Pölten
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 5299000DNBTCYOMV1W76
- Identnumber
- 262803
-
Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Company Description
- Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen is a Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft registered in Austria with the Company reg no FN 77781 i. Its current trading status is "live". It was registered 1892-11-02. and 4 secretaries. The managing director is Dietmar Schöner,Dipl.Ing. Gabriele Zehetner,Margot Schütz,Franz Biber,Dipl.HLFL-Ing. Karl Engelhart, CMC,Mag. Dr. Christian Winter,Sandra Potzmader,Alfons Pitterle, MBA (MCI),Mag. (FH) Markus Zuser.It can be contacted at Linzer Straße 6 .
Get Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870
You are here: Raiffeisenbank Region Schallaburg Egen - Linzer Straße 6, 3382, Loosdorf/ Bez. Melk, AUT, Austria
- 1892-11-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Firmenbuch
- 2024-06-18 Modification
- Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *i wurde ein neues Dokument mit Titel Änderung im Firmenbuch eingetragen und wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen. Die Firma mit der offiziellen Registernummer *i hat ein Protokoll zu einer abgehaltenen Versammlung eingereicht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
-
Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen
Did you know? kompany provides original and official company documents for Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Annual Accounts
Financial data for the last reported full year
Articles of Association
Founding documents
Credit Report by KSV1870
Official credit data
Credit Check by KSV1870
Brief credit details
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2024
-
2024-06-14 - Einladung
keyboard_arrow_right 2023
-
2023-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2023-12-31 - Lagebericht
-
2023-09-20 - Protokoll
-
2023-09-20 - Antrag
-
2023-06-13 - Antrag
keyboard_arrow_right 2022
-
2022-01-20 - Antrag
-
2022-01-20 - Protokoll
-
2022-03-28 - Antrag
-
2022-06-13 - Antrag
-
2022-06-13 - Einladung
-
2022-06-13 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
-
2022-11-28 - Antrag
-
2022-12-05 - Protokoll
-
2022-12-05 - Antrag
-
2022-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2022-12-31 - Lagebericht
-
2022-12-05 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-01-08 - Antrag
-
2021-11-08 - Protokoll
-
2021-11-08 - Antrag
-
2021-09-14 - Antrag
-
2021-10-25 - Musterzeichnung
-
2021-12-31 - Lagebericht
-
2021-11-25 - Antrag
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-12-31 - Lagebericht
-
2020-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2020-11-24 - Liste
-
2020-11-24 - Antrag
-
2020-11-24 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2020-11-24 - Einladung
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-06-25 - Antrag
-
2019-06-25 - Satzungsgegenüberstellung
-
2019-06-25 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
-
2019-06-25 - Einladung
-
2019-12-31 - Lagebericht
-
2019-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2018-03-06 - Protokoll
-
2018-03-06 - Antrag
-
2018-03-06 - Musterzeichnung
-
2018-06-21 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2018-06-21 - Einladung
-
2018-07-11 - Antrag
-
2018-07-11 - Musterzeichnung
-
2018-12-31 - Lagebericht
-
2018-06-21 - Liste
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-06-21 - Antrag
-
2017-03-01 - Protokoll
-
2017-06-21 - Einladung
-
2017-08-10 - Protokoll
-
2017-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2017-08-10 - Antrag
-
2017-12-31 - Lagebericht
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-12-31 - Lagebericht
-
2016-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2016-06-21 - Liste
-
2016-06-21 - Einladung
-
2016-04-27 - Protokoll
-
2016-06-21 - Musterzeichnung
-
2016-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2015-12-31 - Lagebericht
-
2015-07-06 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2015-07-06 - Satzungsgegenüberstellung
-
2015-07-06 - Einladung
-
2015-07-06 - Antrag
-
2015-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-06-17 - Verschmelzungsbilanz
-
2014-06-17 - Zeichnungsbestätigung
-
2014-06-17 - Antrag
-
2014-06-17 - Einladung
-
2014-06-17 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2014-06-17 - Verschmelzungsvertrag
-
2014-02-28 - Antrag
-
2014-09-04 - Bescheid
-
2014-06-17 - Musterzeichnung
-
2014-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2014-12-31 - Lagebericht
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-05-31 - Liste
-
2013-05-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2013-05-31 - Musterzeichnung
-
2013-08-07 - Antrag
-
2013-08-07 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2013-08-07 - Satzungsgegenüberstellung
-
2013-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2013-12-31 - Lagebericht
-
2013-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2013-08-07 - Einladung
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2012-12-31 - Lagebericht
-
2012-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2012-11-13 - Liste
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-05-17 - Antrag
-
2011-05-16 - Liste
-
2011-07-01 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2011-08-08 - Anmeldung zur Eintragung
-
2011-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2011-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2011-12-31 - Lagebericht
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-02-19 - Einladung
-
2010-04-11 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2010-03-21 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2010-03-31 - Einladung
-
2010-04-12 - Liste
-
2010-04-11 - Protokoll
-
2010-05-26 - Bescheid
-
2010-04-12 - Musterzeichnung
-
2010-04-13 - Musterzeichnung
-
2010-02-26 - Verschmelzungsvertrag
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-12-14 - Musterzeichnung
-
2009-12-11 - Protokoll
-
2009-12-07 - Protokoll
-
2009-03-20 - Antrag
-
2009-04-17 - Protokoll
-
2009-04-06 - Einladung
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2008-04-26 - Liste
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-06-03 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2007-06-03 - Liste
-
2007-06-22 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-06-23 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2006-06-13 - Einladung
keyboard_arrow_right 2005
-
2005-10-23 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2005-06-28 - Protokoll
-
2005-07-01 - Protokoll
-
2005-04-07 - Protokoll d.Aufsichtsrates
-
2005-02-22 - Protokoll d.Geschäftsleitersitzung
-
2005-04-19 - Musterfirmazeichnung
-
2005-04-07 - Protokoll d. Vorstandes
keyboard_arrow_right 2004
-
2004-12-03 - Musterfirmazeichnung
-
2004-10-08 - Aufsichtsratsliste
-
2004-11-17 - Musterfirmazeichnung
-
2004-10-24 - Generalversammlungsprotokoll
keyboard_arrow_right 2003
-
2003-10-19 - Generalversammlungsprotokoll
-
2003-10-19 - Aufsichtsratsliste