• AT
  • PwC Wirtschaftsprüfung GmbH - Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT, Austria

Company Information

Company registration number
88248b
Company Status
LIVE
Country
Austria
Registered Address
Donau-City-Straße 7
1220
Wien
AUT
Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT AT

Management

Managing Directors
Mag. Dr. Aslan Milla (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Krieglergasse 17-19/35, 1030, Wien, AUT
Dkfm. Dorotea-Elisabet Rebmann (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Fischerstiege 10/24, 1010, Wien, AUT
Mag. Thomas Strobach (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o PwC Austria Holding AG, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
Mag. Peter Pessenlehner (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Wagnerstraße 26, 2371, Hinterbrühl, AUT
Mag. Ute Unden-Schubert (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Fröschlgasse 10/1, 1190, Wien, AUT
Mag. Horst Bernegger (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Pfeilgasse 3/33, 1080, Wien, AUT
Mag. Friedrich Baumgartner (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Buchenweg 11, 4202, Kirchschlag, AUT
MMag. Frederic Vilain (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Goldeggasse 31/43, 1040, Wien, AUT
Mag. Harald Schindl (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT
Mag.(FH) Werner Stockreiter (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Getreidegasse 6, 2481, Achau, AUT
Mag.Dr. Anton Pichler (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Rettenpacherstraße 32A, 5020, Salzburg, AUT
Dkfm. Timo Steinmetz (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Rembrandtstraße 12/14, 1020, Wien, AUT
Dkfm. (Univ.) Hans Michael Hartmann (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Weyringergasse 3/29, 1040, Wien, AUT
Mag. Alexander Riavitz (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o PwC Österreich GmbH,, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
Mag. Peter Perktold (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o PwC Austria Holding AG, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
Mag.(FH) Christina Decker (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o PwC Österreich GmbH, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
Mag.(FH) Sabine Kutschera (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT
Dipl.-BW (FH) Marius Richter (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
c/o PwC Österreich GmbH, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
Gabor Krüpl, MSc (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT
Mag. Johannes Schmid (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Hafenstraße 2a, 4020, Linz, AUT
Company secretaries
Mag Gerhard Helmreich (PROKURIST/IN)
Kronesgasse 4/2, 1190, Wien, AUT
Mag. Robert Wagner (PROKURIST/IN)
Hornbostelgasse 5/8, 1060, Wien, AUT
Mag. Dietmar Stefan (PROKURIST/IN)
St. Veiter Ring 25C/Top 16, 9020, Klagenfurt am Wörthersee, AUT
Mag. Anton Pürrer (PROKURIST/IN)
Dürauergasse 14/3/16, 1170, Wien, AUT
Mag. Claudia Veit-Graf (PROKURIST/IN)
Hernalser Hauptstraße 156/5, 1170, Wien, AUT
Mag. Friedrich Schwaiger (PROKURIST/IN)
Scheibenbergstraße 38/1/8, 1180, Wien, AUT
Mag. Dieter Neurauter (PROKURIST/IN)
Greutberggasse 16, 1140, Wien, AUT
Dott. Stefano Mulas (PROKURIST/IN)
Bernhard-Wicki-Straße 8, 80636, München, DEU
Mag. (FH) Margit Sternberger (PROKURIST/IN)
c/o PwC Österreich GmbH, 1220, Wien, Donau-City-Straße 7, AUT
MMag. Reinhard Göschl (PROKURIST/IN)
Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
1991-09-18
Age Of Company
1991-09-18 32 years

Ownership

Shareholders
PwC Österreich GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (GESELLSCHAFTER/IN, 80000 EUR, 100%) Donau-City-Straße 7 1220 Wien AUT
Share Capital
80000 EUR
Paidup Capital
80000

Jurisdiction Particularities

Court
Handelsgericht Wien
Previous Names
Price Waterhouse Aktiengesellschaft
Identnumber
1663240
Phone
01 501 88-0

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH Company Description

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Austria with the Company reg no FN 88248 b. Its current trading status is "live". It was registered 1991-09-18. It was previously called Price Waterhouse Aktiengesellschaft. and 10 secretaries. The managing director is Mag. Dr. Aslan Milla,Dkfm. Dorotea-Elisabet Rebmann,Mag. Thomas Strobach,Mag. Peter Pessenlehner,Mag. Ute Unden-Schubert,Mag. Horst Bernegger,Mag. Friedrich Baumgartner,MMag. Frederic Vilain,Mag. Harald Schindl,Mag.(FH) Werner Stockreiter,Mag.Dr. Anton Pichler,Dkfm. Timo Steinmetz,Dkfm. (Univ.) Hans Michael Hartmann,Mag. Alexander Riavitz,Mag. Peter Perktold,Mag.(FH) Christina Decker,Mag.(FH) Sabine Kutschera,Dipl.-BW (FH) Marius Richter,Gabor Krüpl, MSc,Mag. Johannes Schmid.It can be contacted at Donau-City-Straße 7 by phone on 01 501 88-0 .
More information

Get PwC Wirtschaftsprüfung GmbH Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870

You are here: Pwc Wirtschaftsprüfung Gmbh - Donau-City-Straße 7, 1220, Wien, AUT, Austria

1991-09-18 32 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Firmenbuch

  • 2024-03-28 Modification
    • Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *b wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen und wurde ein neues Dokument mit Titel Änderung im Firmenbuch eingetragen. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2024-02-22 Modification
      • Die Firma mit der offiziellen Registernummer *b hat eine Unterschriftenprobe zu Vergleichszwecken eingereicht (Musterzeichnung) und hat eine Änderung in der Gesellschafterstruktur bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
    • 2023-11-14 Modification
      • Die Firma mit der offiziellen Registernummer *b hat eine Änderung in der Gesellschafterstruktur bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for PwC Wirtschaftsprüfung GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Add to Cart
     

    Register Report

    Official proof of the company existence

    Add to Cart
     

    Annual Accounts

    Financial data for the last reported full year

    Add to Cart
     

    Articles of Association

    Founding documents

    Add to Cart
     

    Credit Report by KSV1870

    Official credit data

    Add to Cart
     

    Credit Check by KSV1870

    Brief credit details

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2023-03-27 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2022-01-14 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-06-14 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-11-09 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-10-19 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2022-12-15 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2022-06-27 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-12-20 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2022-12-30 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2022-12-19 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2021-05-26 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2021-01-20 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-01-20 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2021-01-20 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2021-05-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-07-14 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2021-07-14 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-07-14 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2021-08-24 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2021-10-18 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2021-10-18 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2021-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2020-06-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2020-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2020-07-08 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2020-07-08 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2020-10-28 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2020-11-18 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2020-11-25 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2020-12-18 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-10-24 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2019-10-24 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-08-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2019-08-19 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-06-27 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-06-27 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2019-06-27 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2019-07-08 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2019-07-08 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-04-03 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-01-31 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2019-01-31 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2019-01-16 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2019-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2018-04-09 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2018-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2018-10-17 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2018-10-17 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2018-06-26 - Rücktrittserklärung

      Add to Cart
       
    • 2018-01-24 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2018-01-24 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2018-07-13 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-07-20 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2017-03-17 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-12-13 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2017-07-18 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2017-06-28 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2017-08-01 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2017-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2017-03-17 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2017-01-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2017-01-31 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-03-16 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2016-03-16 - Verzichtserklärung

      Add to Cart
       
    • 2016-06-27 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2016-09-08 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-09-07 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2016-09-07 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-12-05 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2016-09-27 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2016-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2016-03-08 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2016-03-16 - Verschmelzungsvertrag

      Add to Cart
       
    • 2016-12-22 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2015-01-30 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-01-26 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-01-26 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2015-09-28 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2015-09-30 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-10-02 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-06-19 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2015-09-17 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-08-13 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2015-03-23 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2015-09-09 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2014-12-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2014-03-27 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2013-03-27 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2013-06-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2013-04-03 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Verschmelzungsvertrag

      Add to Cart
       
    • 2012-03-13 - Protokoll d. Generalversammlung

      Add to Cart
       
    • 2012-03-13 - Übernahmserklärung

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2012-03-06 - Schlussbilanz

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Verzichtserklärung

      Add to Cart
       
    • 2012-06-26 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2012-03-28 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2012-10-25 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2011-03-25 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2011-03-02 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2011-07-01 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2010-09-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2010-12-21 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2009-10-22 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2009-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2009-11-27 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2009-09-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2008-01-08 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2008-05-20 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2008-01-25 - Antrag

      Add to Cart
       
    • 2008-05-20 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2008-06-19 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2008-07-29 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2008-09-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2008-10-28 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2008-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2008-12-02 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2008-12-02 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-03-29 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-03-23 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-03-27 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-03-26 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-03-26 - Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2007-06-04 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-10-05 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-09-07 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2007-10-30 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2007-10-30 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2007-12-05 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2007-12-17 - Beschluss d. Gesellschafter

      Add to Cart
       
    • 2006-04-04 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-06-30 - Ergebnisverwendungsbeschluss

      Add to Cart
       
    • 2006-06-30 - Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss

      Add to Cart
       
    • 2006-07-26 - Protokoll

      Add to Cart
       
    • 2006-03-30 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-04-11 - Musterzeichnung

      Add to Cart
       
    • 2006-02-22 - Bericht

      Add to Cart
       
    • 2005-06-30 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    • 2005-09-28 - Protokoll d. Hauptversammlung

      Add to Cart
       
    expand_less