-
-
STELLANTIS AUTO SAS - 2, BOULEVARD DE L'EUROPE, 78300, POISSY, France
Company Information
- Company registration number
- 542065479
- Company Status
- LIVE
- Country
- France
- Registered Address
- 2
- BOULEVARD DE L'EUROPE
- 78300
- POISSY
- FRANCE 2, BOULEVARD DE L'EUROPE, 78300, POISSY, FRANCE FR
Management
- Officers
-
XAVIER CHEREAU (Président de SAS)
FRANCE 78670 Villennes-sur-Seine - ERNST & YOUNG et Autres (Commissaire aux comptes titulaire)
- DELOITTE & ASSOCIES (Commissaire aux comptes titulaire)
Company Details
- Type of Business
- SAS, société par actions simplifiée
- Incorporated
- 1999-02-11
- Age Of Company 1999-02-11 26 years
- SIC/NACE Code
-
- 2910Z
- Activity
- L'industrie et le commerce automobiles et notamment la conception, le développement, la construction, l'achat et la vente, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles de toutes natures ainsi que la formation professionnelle continue. Transp
Ownership
- Beneficial Owners
- XAVIER CHEREAU
- Share Capital
- 300176800.0 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- Active
- -
- -
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 969500HXH031HJIFGL63
- SIRET
- 54206547900926
- Patents
- 2012-12-20 EN/ELBOWED CASING FOR AN ASSEMBLY FOR THE POST-TREATMENT OF THE EXHAUST GASES OF A COMBUSTION ENGINE COMPRISING TWO HALF SHELLS
- 2012-12-20 EN/METHOD FOR DETECTING A CHANGE OF REDUCING AGENT CANISTER IN AN SCR SYSTEM, EXHAUST LINE AND VEHICLE
This company owns 2 patent(s)
-
STELLANTIS AUTO SAS Company Description
- 2 .
Get STELLANTIS AUTO SAS Registration DetailsArticles of AssociationAnnual AccountsRegister Report
You are here: Stellantis Auto Sas - 2, BOULEVARD DE L'EUROPE, 78300, POISSY, France
- 1999-02-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
Did you know? kompany provides original and official company documents for STELLANTIS AUTO SAS as filed with the government register. Guaranteed.
Registration Details
Records on the company status
Articles of Association
Founding documents
Annual Accounts
Financial data for the last reported full year
Register Report
Official proof of the company existence
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2024
-
2024-06-10 - 2024-06-10
keyboard_arrow_right 2023
-
2023-11-02 - 2023-11-02
keyboard_arrow_right 2022
-
2022-07-13 - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes 2022-07-13
-
2022-10-17 - Changement relatif à la durée de la personne morale 2022-10-17
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-05-07 - 2021-05-07
-
2021-05-12 - Changement(s) d'administrateur(s) 2021-05-12
-
2021-08-04 - Changement de forme juridique 2021-08-04
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-07-27 - 2020-07-27
-
2020-07-28 - 2020-07-28
-
2020-10-03 - 2020-10-03
-
2020-11-27 - 2020-11-27
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-08-10 - non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant 2018-08-10
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-06-28 - Changement de la dénomination sociale 2017-06-28
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-08-10 - Changement de commissaire aux comptes suppléant 2016-08-10
-
2016-12-13 - Changement(s) d'administrateur(s) 2016-12-13
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-02-03 - Démission(s) d'administrateur(s) 2015-02-03
-
2015-04-03 - Cooptation d'administrateurs 2015-04-03
-
2015-09-21 - Changement(s) d'administrateur(s) 2015-09-21
-
2015-12-17 - Modification(s) statutaire(s) 2015-12-17
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-01-15 - Changement relatif à l'objet social 2014-01-15
-
2014-06-13 - Changement de président du conseil d'administration 2014-06-13
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-12-16 - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social 2013-12-16
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-01-04 - Réduction du capital social 2012-01-04
-
2012-05-09 - Changement(s) d'administrateur(s) 2012-05-09
-
2012-09-28 - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social 2012-09-28
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-09-23 - Changement de commissaire aux comptes suppléant 2011-09-23
-
2011-12-15 - Divers 2011-12-15
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-04-21 - changement de Président du conseil d'administration. 2010-04-21
-
2010-12-13 - Changement(s) d'administrateur(s) 2010-12-13
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-02-23 - 2009-02-23
-
2009-09-21 - Changement(s) d'administrateur(s) 2009-09-21
-
2009-09-21 - Nomination(s) d'administrateur(s) 2009-09-21
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-06-16 - Changement de commissaire aux comptes suppléant 2008-06-16
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-05-14 - Changement(s) d'administrateur(s) 2007-05-14
-
2007-11-21 - Changement(s) d'administrateur(s) 2007-11-21
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-05-11 - ENTRE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA ET PEUGEOT CITROEN MOTEURS 2006-05-11
-
2006-06-09 - SUR LA VALEUR DES APPORTS - FUSION PAR VOIE D ABSORPTION DE LA Ste. PEUGEOT CITROEN MOTEURS PAR LA Ste. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA 2006-06-09
-
2006-09-12 - PROJET DE FUSION ABSORPTION AVEC LA SOCIETE PEUGEOT CITROEN MOTEURS 2006-09-12
keyboard_arrow_right 2005
-
2005-06-09 - Nomination de commissaire aux apports 2005-06-09
-
2005-09-23 - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant 2005-09-23
keyboard_arrow_right 2003
-
2003-03-07 - DE NEUILLY SUR SEINE 92200A VELIZY VILLACOUBLAY 78140 2003-03-07
-
2003-10-09 - ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 2003-10-09
-
2003-10-09 - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant 2003-10-09
keyboard_arrow_right 2002
-
2002-03-14 - Transfert du siège social 2002-03-14
-
2002-06-03 - Changement(s) d'administrateur(s) 2002-06-03
-
2002-07-29 - LOI NRE 2002-07-29
-
2002-08-02 - ET LA SOCIETE DJ-34 2002-08-02
-
2002-10-10 - Apport partiel d'actif 2002-10-10
-
2002-11-15 - ET LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE POISSY 2002-11-15
keyboard_arrow_right 2001
-
2001-06-14 - Changement(s) d'administrateur(s) 2001-06-14
-
2001-09-26 - 01O1912 2001-09-26
-
2001-09-26 - 01O1911 2001-09-26
-
2001-11-08 - 2 EX ET LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT 2001-11-08
-
2001-11-08 - 2 EX ET LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN 2001-11-08
-
2001-12-06 - APPORT DE TITRES DE LA SOCIETE PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPANA SA PAR LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN 2001-12-06
-
2001-12-06 - APPORTS DE TITRES DE LA SOCIETE PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPANA SA PAR LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT 2001-12-06
keyboard_arrow_right 2000
-
2000-03-10 - Changement de représentant permanent 2000-03-10
-
2000-03-24 - 2 EX ET LA SOCIETE KSDSE 2000-03-24
-
2000-10-26 - Changement de commissaire aux comptes suppléant 2000-10-26
keyboard_arrow_right 1999
-
1999-01-27 - 28-10-1998 1999-01-27
-
1999-02-04 - - 1999-02-04
-
1999-04-01 - 99O596 1999-04-01
-
1999-05-10 - 2 EX ET LA SOCIETE SOGEDAC 1999-05-10
-
1999-07-19 - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant 1999-07-19
-
1999-09-21 - - 1999-09-21
-
1999-11-30 - 2 EX ET LA SOCIETE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA 1999-11-30
keyboard_arrow_right 1998
-
1998-10-07 - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social 1998-10-07
-
1998-11-09 - Changement de président 1998-11-09
-
1998-11-20 - PAR LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN - 1998-11-20
-
1998-11-20 - 1998-11-20
-
1998-11-23 - - 1998-11-23
-
1998-11-23 - Augmentation du capital social 1998-11-23
-
1998-12-11 - (SUR LES APPORTS) - PAR LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT 1998-12-11
-
1998-12-12 - 1998-12-12
keyboard_arrow_right 1997
-
1997-02-25 - Changement de représentant permanent 1997-02-25
-
1997-09-05 - Augmentation du capital social 1997-09-05
keyboard_arrow_right 1994
-
1994-09-22 - Divers 1994-09-22
keyboard_arrow_right 1993
-
1993-12-01 - Transfert du siège social d'un greffe extérieur NOUVEAU SIEGE : 105 AVENUE GABRIEL PERI 92 MALAKOFF 1993-12-01
-
1993-12-27 - Divers 1993-12-27